Bylaws
Bylaws are municipal laws created under the authority of the Municipal Government Act to maintain the health, safety, and wellness of the community. The Municipal District of Bonnyville’s bylaws are enacted by M.D. Council and maintained by the Legislative and Information Services Department.
Bylaws, as presented here, have no legal sanction and are presented solely for the purpose of research and ease of reference. If you require an official copy of a bylaw, please contact the M.D. Legislative and Information Services department.
Public Safety
Transportation, Utilities and Services
Finance and Taxes
- Bylaw 1745 Mill Rate Bylaw 2020
- Bylaw 1775 Tax Rate Bylaw 2021
- Bylaw 1786 Master Rates Bylaw (Amends Bylaws 1200, 1325, 1371, 1627, 1666, 1668 & 1717; Amended by Bylaw 1833)
- Bylaw 1800 Tax Rate Bylaw 2022
- Bylaw 1833 Amending Master Rates Bylaw (Amends Bylaw 1786)
- Bylaw 1844 Tax Rate Bylaw 2023
- Bylaw 1846 Unpaid Tax Penalty Bylaw
General Governance
- Bylaw 808 Licensing and Regulation of Concerts Bylaw
- Bylaw 1120 Appointment of Chief Administrative Officer Bylaw (Amended by Bylaw 1329)
- Bylaw 1200 Structure and Fee FOIP Act Schedule Bylaw (Amended by Bylaw 1786)
- Bylaw 1300 Municipal Addressing System Bylaw
- Bylaw 1329 Appointment of Chief Administrative Officer Bylaw (Amends Bylaw 1120)
- Bylaw 1658 Retention and Disposal of Municipal Records Bylaw
- Bylaw 1670 Subdivision and Development Appeal Board Bylaw (Amended by Bylaw 1807)
- Bylaw 1742 Local Assessment Review Board Bylaw (Amended by Bylaw 1806)
- Bylaw 1743 Composite Assessment Review Board Bylaw (Amended by Bylaw 1806)
- Bylaw 1748 Boards and Committees Bylaw (Amended by Bylaw 1793 & Bylaw 1808)
- Bylaw 1793 Amending and Repealing Governance Bylaw (Amends Bylaw 1748 & Bylaw 1787)
- Bylaw 1806 Amending Assessment Review Board Bylaw (Amends Bylaw 1742 & Bylaw 1743)
- Bylaw 1807 Amending Subdivision Development Appeal Board Bylaw (Amends Bylaw 1670)
- Bylaw 1808 Amending Boards and Committees Bylaw (Amends Bylaw 1748)
- Bylaw 1830 - Public Notification Bylaw
Council
Municipal Planning
Municipal Development Plans
Intermunicipal Development Plans
Intermunicipal Collaboration Frameworks
Area Structure Plans
- Bylaw 768 Fort Kent Area Structure Plan Bylaw (Amended by Bylaw 870)
- Bylaw 777 Muriel Lake Area Structure Plan Bylaw (Amended by Bylaws 806, 829, 845, 893 & 900)
- Bylaw 806 Muriel Lake Area Structure Plan Bylaw (Amends Bylaw 777)
- Bylaw 829 Muriel Lake Area Structure Plan Bylaw (Amends Bylaw 777)
- Bylaw 836 Chickenhill Lake Area Structure Plan Bylaw (Amended by Bylaw 897)
- Bylaw 845 Muriel Lake Area Structure Plan Bylaw (Amends Bylaw 777)
- Bylaw 862 Frost Homes Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 863 David Industrial Park Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 881 Miron Industrial Park Area Structure Plan Bylaw (Amended by Bylaw 904)
- Bylaw 886 Belvedere Industrial Park Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 887 Dery Industrial Park Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 893 Muriel Lake Area Structure Plan Bylaw (Amends Bylaw 777)
- Bylaw 897 Chickenhill Lake Area Structure Plan Bylaw (Amends Bylaw 836)
- Bylaw 900 Muriel Lake Area Structure Plan Bylaw (Amends Bylaw 777)
- Bylaw 904 Miron Industrial Park Area Structure Plan Bylaw (Amends Bylaw 881)
- Bylaw 923 Moose Lake Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1109 Lakeview Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1210 NW 19-61-5-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1216 Pt of SW16-61-5-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1230 East 1/2 - 34-63-2-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1239 Highway 55 Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1242 Chatwin Lake Country Residential Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1259 SE 18-61-6-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1284 Crawford Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1297 Cherry Ridge Estates Phase 2 Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1298 Pt of SE 16-63-2-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1313 Barreyre Lake Developments Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1318 NW-20-63-3-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1332 Moose Lake Meadows Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1341 Crane Lake Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1342 Pt of NW 1 & SW 12-62-2-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1348 Pt of NW 10-61-5-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1349 Pt of SW 2-63-1-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1352 Pt of NE 7-61-6-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1354 Pt of SW 15-62-1-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1365 Pt of South 1/2 20-61-5-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1373 Grand Haven Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1375 Pt of NE 16-63-3-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1389 Cherry Hill Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1390 Countryside Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1400 Aspen Grove Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1401 Hillside Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1427 Ringuette Industrial Park Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1434 Ansell Ridge Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1435 West 55 Industrial Park Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1442 Pt of NE-24-62-2-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1443 Cold Lake Industrial Park Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1446 Lefebvre Country Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1451 Within Pt of SW 8-61-6- W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1459 Hills of Cold Lake Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1463 Lakeside Village Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1464 Estates of Long Bay Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1465 Signature Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1466 3D Industrial Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1467 Wood Creek RV Resort Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1468 Fawn Ridge Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1469 Riverhurst Subdivision Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1470 White Rose Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1498 Matichuk Industrial Subdivision Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1512 Ethel Lake Area Structure Plan Bylaw (Repeals Ministerial Order #49/82)
- Bylaw 1526 Atherton Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1537 Pt NE 15-64-3-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1540 Fortier Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1545 Pt of SE 10-61-6-W4M Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1573 Osprey Ridge Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1578 Fairway Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1579 Sun Ridge Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1580 Silver Ridge Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1582 Goodhope Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1583 Morris Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1598 LaCorey Park Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1599 Country Road Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1600 Woodlands of Windermere Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1602 River Ridge Estastes Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1606 Lynx Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1612 Haven Hills Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1613 New Haven Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1614 Aurora Borealis Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1633 Green Hills Estates Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1693 Highway 28 and Highway 41 Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1749 Fort Kent Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1782 La Corey Major Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1804 Ardmore Area Structure Plan Bylaw
- Bylaw 1805 Cherry Grove Area Structure Plan Bylaw (Repeals Ministerial Order #307/88)
- Bylaw 1811 Aurora Borealis Area Structure Plan Bylaw
Official bylaws, available from the M.D. Legislative and Information Services department, must be consulted for purposes of accurately interpreting and applying the law.
Contact Us
-
Legislative and Information Services
P:780-826-3171
EmailFor information regarding enforcement of an M.D. Bylaw, please contact Public Safety at 780-826-3171.